Changes to our website — to find out why access to some data now requires a login, click here
The Open Database Of The Corporate World

ATLANTIS COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS SA

Gazette notices

Date Publication Notice Classification
2016-06-17 Boletín Oficial del Registro Mercantil (Spain) APODERAD.SOL: PEREZ ARIAS CARLOS APODERAD.SOL: RODRIGUEZ CELADES FRANCESC Nombramientos details
2017-01-23 Boletín Oficial del Registro Mercantil (Spain) Extinción details
2016-08-01 Boletín Oficial del Registro Mercantil (Spain) CR DE RUBI,72-74,EDIFICIO HORIZON (SANT CUGAT DEL VALLES). Cambio de domicilio social details
2017-01-23 Boletín Oficial del Registro Mercantil (Spain) DTOR.GENERAL: FRANCOIS MARTIN PRESID.JUNTA: GERMAIN JEAN PRESID.JUNTA: JEAN G... Revocaciones details
2014-01-20 Boletín Oficial del Registro Mercantil (Spain) CONSEJERO: MARTINE ROUX Nombramientos details
2015-11-18 Boletín Oficial del Registro Mercantil (Spain) AUDIT.CUENT.: MAZARS AUDITORES SLP Nombramientos details
2010-03-11 Boletín Oficial del Registro Mercantil (Spain) MODIFICACION Y REFUNDICION DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. Modificaciones estatutarias details
2015-04-22 Boletín Oficial del Registro Mercantil (Spain) VICEPRESIDEN: HELIOS INSA CONSEJERO: HELIOS INSA CONSEJERO: PHILIPPE DA COSTA Nombramientos details
2012-08-22 Boletín Oficial del Registro Mercantil (Spain) CONS. DELEG.: CHRISTIAN CORTES PRESIDENTE: CHRISTIAN CORTES Nombramientos details
2010-03-30 Boletín Oficial del Registro Mercantil (Spain) APODERADO: SUBIRATS COMPTE JAUME Revocaciones details
2009-11-12 Boletín Oficial del Registro Mercantil (Spain) CONS. DELEG.: LOUIS AVINENS Nombramientos details
2016-03-08 Boletín Oficial del Registro Mercantil (Spain) APODERADO: RIZOS ASENSIO LYDIA Revocaciones details
2015-10-30 Boletín Oficial del Registro Mercantil (Spain) APOD.SOL/MAN: GONZALVO MARTI FERRAN Nombramientos details
2015-09-09 Boletín Oficial del Registro Mercantil (Spain) VICEPRESIDEN: HELIOS INSA CONSEJERO: CHRISTOPHE PENOUTY CONSEJERO: PHILIPPE D... Revocaciones details
2014-01-20 Boletín Oficial del Registro Mercantil (Spain) CONS. DELEG.: CHRISTIAN CORTES Nombramientos details
2012-02-17 Boletín Oficial del Registro Mercantil (Spain) CONSEJERO: DONATO DEGANUTTI Revocaciones details
2016-03-22 Boletín Oficial del Registro Mercantil (Spain) APODERAD.SOL: GONZALVO MARTI FERRAN APODERAD.SOL: OLIVIER TROTTEMANT APODERAD... Nombramientos details
2010-09-17 Boletín Oficial del Registro Mercantil (Spain) Importe reducción: 9.176.330,24 Euros. Resultante Suscrito: 32.501.760,00 Euros. Reducción de capital details
2010-03-30 Boletín Oficial del Registro Mercantil (Spain) APODERADO: HITA PASCUAL ANTONIO Revocaciones details
2010-03-30 Boletín Oficial del Registro Mercantil (Spain) APODERADO: FRANCOIS JEAN POMMERET Nombramientos details
Hide historic records