Changes to our website — to find out why access to some data now requires a login, click here
The Open Database Of The Corporate World

JC DECAUX ATLANTIS SOCIEDAD ANONIMA

Company Number
35473750
Jurisdiction
Spain
Registry Page
Please log in for link to primary source
Source Spanish Mercantile Registry, https://www.registradores.org/mercant..., 10 Jul 2011

Gazette notices

Date Publication Notice Classification
2020-11-10 Boletín Oficial del Registro Mercantil (Spain) Apo.Sol.: MARTINEZ CAÑAS FRANCISCO Apo.Sol.: MARTINEZ SIMON JAVIER ALFONSO Ap... Revocaciones details
2020-11-10 Boletín Oficial del Registro Mercantil (Spain) Apo.Sol.: RODENAS PEREZ SOFIA Apo.Sol.: GARRIDO-LESTACHE GONZALEZ ALFONSO Apo... Nombramientos details
2020-03-16 Boletín Oficial del Registro Mercantil (Spain) Consejero: PACCALIN JEAN LOUIS Consejero: DECAUX JEAN SEBASTIEN Con.Delegado:... Ceses/Dimisiones details
2020-03-16 Boletín Oficial del Registro Mercantil (Spain) Consejero: ROUBAUD ALEXANDRE ANDRE Consejero: PRIGENT STEPHANE FRANCOIS MARIE... Nombramientos details
2020-01-08 Boletín Oficial del Registro Mercantil (Spain) Apo.Sol.: INOCENTE RODRIGUEZ JUAN MANUEL Apo.Sol.: HERRERA MARTIN JOSE LUIS A... Nombramientos details
2017-06-27 Boletín Oficial del Registro Mercantil (Spain) Consejero: LOPEZ ORTUÑO ISABEL Consejero: CABRE DE LEON ALBERTO Consejero: LO... Ceses/Dimisiones details
2017-06-27 Boletín Oficial del Registro Mercantil (Spain) Consejero: CABRE DE LEON ALBERTO Consejero: PACCALIN JEAN LOUIS Consejero: CA... Nombramientos details
2017-06-27 Boletín Oficial del Registro Mercantil (Spain) Apo.Sol.: MARTINEZ SIMON JAVIER ALFONSO Apo.Sol.: RODENAS PEREZ SOFIA Apo.Sol... Nombramientos details
2017-06-27 Boletín Oficial del Registro Mercantil (Spain) Apo.Manc.: LOPEZ ORTUÑO ISABEL Revocaciones details
2017-06-28 Boletín Oficial del Registro Mercantil (Spain) Apo.Manc.: BARON THAIDIGSMANN CARLOS Nombramientos details
2017-08-14 Boletín Oficial del Registro Mercantil (Spain) Apo.Sol.: SOLAUN AIS MARIA JESUS Apo.Sol.: CARPINTERO BARROSO ELENA Apo.Sol.:... Nombramientos details
2011-08-30 Boletín Oficial del Registro Mercantil (Spain) Consejero: DECAUX JEAN CHARLES Con.Delegado: DECAUX JEAN CHARLES Presidente: ... Ceses/Dimisiones details
2012-08-13 Boletín Oficial del Registro Mercantil (Spain) Consejero: CABRE JIMENEZ JORGE Nombramientos details
2012-02-14 Boletín Oficial del Registro Mercantil (Spain) Artículo de los estatutos: 5. Capital.-. Artículo de los estatutos: 5. Capita... Modificaciones estatutarias details
2011-04-15 Boletín Oficial del Registro Mercantil (Spain) Artículo de los estatutos: 3. Domicilio.-. Modificaciones estatutarias details
2010-04-05 Boletín Oficial del Registro Mercantil (Spain) Apo.Man.Soli: SANCHEZ OLAVARRIA LUIS Revocaciones details
2012-08-13 Boletín Oficial del Registro Mercantil (Spain) Consejero: LANG LENTON ARTURO Ceses/Dimisiones details
2012-02-14 Boletín Oficial del Registro Mercantil (Spain) Importe reducción: 629,75 Euros. Resultante Suscrito: 382.500,00 Euros. Reducción de capital details
2011-08-30 Boletín Oficial del Registro Mercantil (Spain) Consejero: DECAUX JEAN SEBASTIAN Con.Delegado: DECAUX JEAN SEBASTIAN Presiden... Nombramientos details
2011-04-15 Boletín Oficial del Registro Mercantil (Spain) PROL DE LA CALLE SAN PAULO S/N - NAVE 5 POLIGONO I (PALMAS DE GRAN CANARIA (LAS. Cambio de domicilio social details

* While we strive to keep this information correct and up-to-date, it is not the primary source, and the company registry (see source, above) should always be referred to for definitive information
Data on this page last changed November 10 2020

Problem/question about this data? Click here

API Open Data

For access please Log in / Sign up

OpenCorporates
A very different type of data company
Find out more