2019-11-13
|
Boletín Oficial del Registro Mercantil (Spain)
|
Sociedades absorbidas: DIGILANT MARKETING SL. DIGILANT SPAIN SL.
|
Fusión por absorción
|
|
details
|
2019-11-13
|
Boletín Oficial del Registro Mercantil (Spain)
|
LA PRESTACION DE SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET; LA CREACION, GESTION Y DESAR...
|
Cambio de objeto social
|
|
details
|
2019-11-13
|
Boletín Oficial del Registro Mercantil (Spain)
|
Capital: 2.231.594,44 Euros. Resultante Suscrito: 2.841.783,30 Euros.
|
Ampliación de capital
|
|
details
|
2019-11-13
|
Boletín Oficial del Registro Mercantil (Spain)
|
REBOLD MARKETING AND COMMUNICATION S.L.
|
Cambio de denominación social
|
|
details
|
2019-11-13
|
Boletín Oficial del Registro Mercantil (Spain)
|
MODIFICADOS Y REFUNDIDOS LOS ESTATUTOS SOCIALES EN FECHA 30 DE JUNIO DE 2.019.
|
Modificaciones estatutarias
|
|
details
|
2019-07-25
|
Boletín Oficial del Registro Mercantil (Spain)
|
De conformidad con lo dispuesto en el art. 43 de la Ley 3/2009, de 3 de abril...
|
OTROS ANUNCIOS Y AVISOS LEGALES
|
|
details
|
2019-05-13
|
Boletín Oficial del Registro Mercantil (Spain)
|
APOD.SOL/MAN: CHARLOTTE BOUCHET APOD.SOL/MAN: RODES MIRACLE DAVID APOD.SOL/MA...
|
Nombramientos
|
|
details
|
2019-05-13
|
Boletín Oficial del Registro Mercantil (Spain)
|
APODERAD.SOL: GUILLOT PICHOT SERGI
|
Revocaciones
|
|
details
|
2017-12-19
|
Boletín Oficial del Registro Mercantil (Spain)
|
CONSEJERO: RODES MIRACLE JUAN SECRETARIO: RODES MIRACLE JUAN
|
Nombramientos
|
|
details
|
2017-12-19
|
Boletín Oficial del Registro Mercantil (Spain)
|
APODERAD.SOL: GUILLOT PICHOT SERGI
|
Nombramientos
|
|
details
|
2017-12-19
|
Boletín Oficial del Registro Mercantil (Spain)
|
CONSEJERO: GUILLOT PICHOT SERGI CONS. DELEG.: GUILLOT PICHOT SERGI SECRETARIO...
|
Revocaciones
|
|
details
|
2018-03-06
|
Boletín Oficial del Registro Mercantil (Spain)
|
|
Nombramientos
|
|
details
|
2009-08-05
|
Boletín Oficial del Registro Mercantil (Spain)
|
AUDIT.CUENT.: AUDIHISPANA GRANT THORNTON SL
|
Nombramientos
|
|
details
|
2009-08-05
|
Boletín Oficial del Registro Mercantil (Spain)
|
APODERADO: CASCANT MOLINA DAVID
|
Nombramientos
|
|
details
|
2011-09-29
|
Boletín Oficial del Registro Mercantil (Spain)
|
SECR.NO CONS: RODES MIRACLE DAVID VICEPRESIDEN: RODES VILA GONZALO CONSEJERO:...
|
Revocaciones
|
|
details
|
2010-01-28
|
Boletín Oficial del Registro Mercantil (Spain)
|
Importe reducción: 5.838,84 Euros. Resultante Suscrito: 1.567.250,28 Euros.
|
Reducción de capital
|
|
details
|
2011-01-03
|
Boletín Oficial del Registro Mercantil (Spain)
|
Importe reducción: 1.044.833,52 Euros. Resultante Suscrito: 522.416,76 Euros.
|
Reducción de capital
|
|
details
|
2013-10-18
|
Boletín Oficial del Registro Mercantil (Spain)
|
ART.19:SISTEMA RETRIBUTIVO DEL ORGANO DE ADMINISTRACION SOCIAL.
|
Modificaciones estatutarias
|
|
details
|
2009-11-12
|
Boletín Oficial del Registro Mercantil (Spain)
|
APODERADO: GUILLOT PICHOT SERGI
|
Nombramientos
|
|
details
|
2016-03-14
|
Boletín Oficial del Registro Mercantil (Spain)
|
APODERAD.SOL: VASALLO GOMEZ JOSE LUIS APODERAD.SOL: MENDEZ ORTEGA LAURA
|
Nombramientos
|
|
details
|