Changes to our website — to find out why access to some data now requires a login, click here
The Open Database Of The Corporate World

ACCIONA BLADES SA

Gazette notices

Date Publication Notice Classification
2018-05-30 Boletín Oficial del Registro Mercantil (Spain) Apoderado: LECUMBERRI EUSA ALFREDO Apoderado: GAINZA DE TORO LUIS Apoderado: ... Revocaciones details
2018-06-28 Boletín Oficial del Registro Mercantil (Spain) NORDEX BLADES SPAIN SA. Cambio de denominación social details
2018-05-30 Boletín Oficial del Registro Mercantil (Spain) Apoderado: GUZMAN LOPEZ DE LAMADRID JOSE IGNACIO Apoderado: TERUEL MINA ENRIQ... Nombramientos details
2016-05-18 Boletín Oficial del Registro Mercantil (Spain) Apoderado: APODERADA CORPORATIVA GENERAL SA Revocaciones details
2016-05-18 Boletín Oficial del Registro Mercantil (Spain) Adm. Mancom.: ACCIONA DESARROLLO CORPORATIVO S Ceses/Dimisiones details
2017-04-04 Boletín Oficial del Registro Mercantil (Spain) Apoderado: CHIVITE FERNANDEZ FRANCISCO JAVIER Apoderado: EQUISOAIN JANARIZ VI... Nombramientos details
2016-05-18 Boletín Oficial del Registro Mercantil (Spain) POLIG INDUSTRIAL BARASOAIN, PARCELA 2 (BARASOAIN). Cambio de domicilio social details
2016-05-18 Boletín Oficial del Registro Mercantil (Spain) Adm. Mancom.: BLANCO DIEGUEZ JOSE LUIS Adm. Mancom.: LANDA ESPARZA PATXI XABIER Nombramientos details
2017-07-07 Boletín Oficial del Registro Mercantil (Spain) Auditor: KPMG AUDITORES SL Cancelaciones de oficio de nombramientos details
2017-04-04 Boletín Oficial del Registro Mercantil (Spain) Apoderado: LOPEZ ROSAIN RAUL Revocaciones details
2017-07-07 Boletín Oficial del Registro Mercantil (Spain) Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL Nombramientos details
2013-11-04 Boletín Oficial del Registro Mercantil (Spain) DON JOSE JULIO FIGUEROA GOMEZ DE SALAZAR y DOÑA MARIA OLGA CORELLA HURTADO, c... Otros conceptos details
2014-01-16 Boletín Oficial del Registro Mercantil (Spain) Suscrito: 1.613.822,00 Euros. Desembolsado: 1.613.822,00 Euros. Resultante Su... Ampliación de capital details
2010-05-03 Boletín Oficial del Registro Mercantil (Spain) Suscrito: 462.499,00 Euros. Desembolsado: 462.499,00 Euros. Resultante Suscri... Ampliación de capital details
2015-02-13 Boletín Oficial del Registro Mercantil (Spain) Auditor: KPMG AUDITORES SL Reelecciones details
2011-06-22 Boletín Oficial del Registro Mercantil (Spain) Auditor: KPMG AUDITORES S Nombramientos details
2012-11-29 Boletín Oficial del Registro Mercantil (Spain) Apoderado: BLANCO DIEGUEZ JOSE LUIS Apoderado: PULPEIRO MORI PABLO JOSE Apode... Nombramientos details
2012-11-29 Boletín Oficial del Registro Mercantil (Spain) Apoderado: GEMBERO USTARROZ FERMIN Apoderado: MONASTERIO LASA FEDERICO Apoder... Revocaciones details
2016-02-03 Boletín Oficial del Registro Mercantil (Spain) Auditor: KPMG AUDITORES SL Reelecciones details
2014-05-22 Boletín Oficial del Registro Mercantil (Spain) Designado a Don José Luis Blanco Diéguez representante físico de la Administr... Otros conceptos details
Hide historic records