Changes to our website — to find out why access to some data now requires a login, click here
The Open Database Of The Corporate World

MGI COUTIER ESPAÑA SL

Gazette notices

Date Publication Notice Classification
2019-01-21 Boletín Oficial del Registro Mercantil (Spain) AKWEL VIGO SPAIN SL. Cambio de denominación social details
2016-09-01 Boletín Oficial del Registro Mercantil (Spain) Apoderado: SANCHEZ ROGER Apo.Manc.: BARQUERO RODRIGUEZ MIGUEL DAVID Apo.Manc.... Revocaciones details
2016-09-01 Boletín Oficial del Registro Mercantil (Spain) Apo.Sol.: BARQUERO RODRIGUEZ MIGUEL DAVID Consejero: BARQUERO RODRIGUEZ MIGUE... Nombramientos details
2016-09-01 Boletín Oficial del Registro Mercantil (Spain) Secretario: GONZALEZ MOSQUERA CARLOS Consejero: SANCHEZ ROGER Consejero: THOM... Ceses/Dimisiones details
2010-09-01 Boletín Oficial del Registro Mercantil (Spain) Apo.Manc.: DOMINGUEZ REGO FRANCISCO Revocaciones details
2014-04-30 Boletín Oficial del Registro Mercantil (Spain) Apo.Sol.: SANCHEZ ROGER Apo.Manc.: COEDO GONZALEZ BEATRIZ Apo.Manc.: BARQUERO... Revocaciones details
2015-07-03 Boletín Oficial del Registro Mercantil (Spain) Secretario: GONZALEZ MOSQUERA CARLOS Ceses/Dimisiones details
2009-07-08 Boletín Oficial del Registro Mercantil (Spain) Apo.Sol.: GIGOT CHRISTIAN GILBERT Nombramientos details
2009-02-05 Boletín Oficial del Registro Mercantil (Spain) Auditor: MAZARS AUDITORES SL Reelecciones details
2016-03-21 Boletín Oficial del Registro Mercantil (Spain) Auditor: MAZARS AUDITORES SLP Nombramientos details
2014-04-30 Boletín Oficial del Registro Mercantil (Spain) Apoderado: SANCHEZ ROGER Apo.Manc.: BARQUERO RODRIGUEZ MIGUEL DAVID Apo.Manc.... Nombramientos details
2009-11-19 Boletín Oficial del Registro Mercantil (Spain) Consejero: ORONCE THOMASSET JEAN LOUIS Consejero: COUTIER ANDRE Consejero: CO... Reelecciones details
2011-03-22 Boletín Oficial del Registro Mercantil (Spain) Apoderado: SANCHEZ ROGER Nombramientos details
2011-03-22 Boletín Oficial del Registro Mercantil (Spain) Apo.Sol.: GIGOT CHRISTIAN GILBERT Revocaciones details
2012-09-19 Boletín Oficial del Registro Mercantil (Spain) Apo.Sol.: SANCHEZ ROGER Apo.Manc.: COEDO GONZALEZ BEATRIZ Apo.Manc.: BARQUERO... Nombramientos details
2009-12-11 Boletín Oficial del Registro Mercantil (Spain) Auditor: MAZARS AUDITORES SL Reelecciones details
2015-07-03 Boletín Oficial del Registro Mercantil (Spain) Secretario: GONZALEZ MOSQUERA CARLOS Consejero: SANCHEZ ROGER Consejero: THOM... Nombramientos details
2013-02-08 Boletín Oficial del Registro Mercantil (Spain) Auditor: MAZARS AUDITORES SLP Reelecciones details
2012-09-19 Boletín Oficial del Registro Mercantil (Spain) Apoderado: SANCHEZ ROGER Apo.Manc.: COEDO GONZALEZ BEATRIZ Apo.Manc.: GONZALE... Revocaciones details
2009-02-05 Boletín Oficial del Registro Mercantil (Spain) Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL Cancelaciones de oficio de nombramientos details
Hide historic records