Changes to our website — to find out why access to some data now requires a login, click here
The Open Database Of The Corporate World

FAIVELEY TRANSPORT IBERICA SA

Company Number
28163335
Company Type
Sociedad Anónima
Jurisdiction
Spain
Controlling Company
WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIES CORPORATION
Registry Page
Please log in for link to primary source
Source Spanish Mercantile Registry, https://www.registradores.org/mercant..., 27 Jun 2011

Branches


Gazette notices

Date Publication Notice Classification
2021-05-25 Boletín Oficial del Registro Mercantil (Spain) Adm. Mancom.: SPENCER JEROME PAUL Ceses/Dimisiones details
2021-05-25 Boletín Oficial del Registro Mercantil (Spain) Adm. Mancom.: GAUR SAMEER Nombramientos details
2020-12-24 Boletín Oficial del Registro Mercantil (Spain) Auditor: ERNST & YOUNG SL Cancelaciones de oficio de nombramientos details
2020-12-24 Boletín Oficial del Registro Mercantil (Spain) Auditor: ERNST YOUNG SL Nombramientos details
2019-08-29 Boletín Oficial del Registro Mercantil (Spain) Apoderado: GENE FERRE JOSEP MARIA Apo.Man.Soli: DE LA TORRE MONGUIO JESUS Apo... Revocaciones details
2019-08-27 Boletín Oficial del Registro Mercantil (Spain) Auditor: PRICE WATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL Cancelaciones de oficio de nombramientos details
2019-08-29 Boletín Oficial del Registro Mercantil (Spain) Apo.Sol.: SANAHUJA CAPDEVILA MARGARIDA Nombramientos details
2019-09-25 Boletín Oficial del Registro Mercantil (Spain) Apo.Manc.: CACERES CANO RAFAEL Revocaciones details
2019-08-28 Boletín Oficial del Registro Mercantil (Spain) Ratificada a DOÑA MARGARIDA SANAHUJA CAPDEVILA, en su cargo de SECRETARIA NO ... Otros conceptos details
2019-08-29 Boletín Oficial del Registro Mercantil (Spain) Adm. Mancom.: SPENCER JER-ME PAUL Adm. Mancom.: VIDAL ALEXANDRE Nombramientos details
2019-08-29 Boletín Oficial del Registro Mercantil (Spain) Apoderado: CARVALHO GONZCALVES DE FREITAS JOAO Revocaciones details
2019-08-29 Boletín Oficial del Registro Mercantil (Spain) Justificacion de no aprobacion de cuentas del ejercicio 2017 mediante certifi... Articulo 378.5 del Reglamento del Registro Mercantil details
2019-08-28 Boletín Oficial del Registro Mercantil (Spain) Consejero: SPENCER JER-ME PAUL Consejero: VIDAL ALEXANDRE Presidente: SPENCER... Nombramientos details
2019-08-29 Boletín Oficial del Registro Mercantil (Spain) Secretario: SANAHUJA CAPDEVILA MARGARIDA Consejero: RAMBAUD MEASSON STEPHANE ... Ceses/Dimisiones details
2019-08-28 Boletín Oficial del Registro Mercantil (Spain) Consejero: FRANCOIS CAUSSE REMI Consejero: JEAN MELI VICENT Presidente: FRANC... Ceses/Dimisiones details
2019-08-29 Boletín Oficial del Registro Mercantil (Spain) Apo.Sol.: VIEIRA FERREIRA LUIS MIGUEL Nombramientos details
2019-08-29 Boletín Oficial del Registro Mercantil (Spain) Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL Cancelaciones de oficio de nombramientos details
2019-09-25 Boletín Oficial del Registro Mercantil (Spain) Apoderado: ABECASIS HENELDE DANIEL YEHUDA Nombramientos details
2019-08-29 Boletín Oficial del Registro Mercantil (Spain) Auditor: ERNST & YOUNG SL Nombramientos details
2019-08-27 Boletín Oficial del Registro Mercantil (Spain) Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL Nombramientos details

Identifiers

Identifier System Identifier Categories
LEI 213800CAZ48V8ZNT7669 details


* While we strive to keep this information correct and up-to-date, it is not the primary source, and the company registry (see source, above) should always be referred to for definitive information
Data on this page last changed February 29 2024

Problem/question about this data? Click here

API Open Data

For access please Log in / Sign up

OpenCorporates
A very different type of data company
Find out more