Changes to our website — to find out why access to some data now requires a login, click here
The Open Database Of The Corporate World

JC DECAUX ATLANTIS SOCIEDAD ANONIMA

Gazette notices

Date Publication Notice Classification
2020-11-10 Boletín Oficial del Registro Mercantil (Spain) Apo.Sol.: MARTINEZ CAÑAS FRANCISCO Apo.Sol.: MARTINEZ SIMON JAVIER ALFONSO Ap... Revocaciones details
2020-11-10 Boletín Oficial del Registro Mercantil (Spain) Apo.Sol.: RODENAS PEREZ SOFIA Apo.Sol.: GARRIDO-LESTACHE GONZALEZ ALFONSO Apo... Nombramientos details
2020-03-16 Boletín Oficial del Registro Mercantil (Spain) Consejero: PACCALIN JEAN LOUIS Consejero: DECAUX JEAN SEBASTIEN Con.Delegado:... Ceses/Dimisiones details
2020-03-16 Boletín Oficial del Registro Mercantil (Spain) Consejero: ROUBAUD ALEXANDRE ANDRE Consejero: PRIGENT STEPHANE FRANCOIS MARIE... Nombramientos details
2020-01-08 Boletín Oficial del Registro Mercantil (Spain) Apo.Sol.: INOCENTE RODRIGUEZ JUAN MANUEL Apo.Sol.: HERRERA MARTIN JOSE LUIS A... Nombramientos details
2017-06-27 Boletín Oficial del Registro Mercantil (Spain) Consejero: LOPEZ ORTUÑO ISABEL Consejero: CABRE DE LEON ALBERTO Consejero: LO... Ceses/Dimisiones details
2017-06-27 Boletín Oficial del Registro Mercantil (Spain) Consejero: CABRE DE LEON ALBERTO Consejero: PACCALIN JEAN LOUIS Consejero: CA... Nombramientos details
2017-06-27 Boletín Oficial del Registro Mercantil (Spain) Apo.Sol.: MARTINEZ SIMON JAVIER ALFONSO Apo.Sol.: RODENAS PEREZ SOFIA Apo.Sol... Nombramientos details
2017-06-27 Boletín Oficial del Registro Mercantil (Spain) Apo.Manc.: LOPEZ ORTUÑO ISABEL Revocaciones details
2017-06-28 Boletín Oficial del Registro Mercantil (Spain) Apo.Manc.: BARON THAIDIGSMANN CARLOS Nombramientos details
2017-08-14 Boletín Oficial del Registro Mercantil (Spain) Apo.Sol.: SOLAUN AIS MARIA JESUS Apo.Sol.: CARPINTERO BARROSO ELENA Apo.Sol.:... Nombramientos details
2011-08-30 Boletín Oficial del Registro Mercantil (Spain) Consejero: DECAUX JEAN CHARLES Con.Delegado: DECAUX JEAN CHARLES Presidente: ... Ceses/Dimisiones details
2012-08-13 Boletín Oficial del Registro Mercantil (Spain) Consejero: CABRE JIMENEZ JORGE Nombramientos details
2012-02-14 Boletín Oficial del Registro Mercantil (Spain) Artículo de los estatutos: 5. Capital.-. Artículo de los estatutos: 5. Capita... Modificaciones estatutarias details
2011-04-15 Boletín Oficial del Registro Mercantil (Spain) Artículo de los estatutos: 3. Domicilio.-. Modificaciones estatutarias details
2010-04-05 Boletín Oficial del Registro Mercantil (Spain) Apo.Man.Soli: SANCHEZ OLAVARRIA LUIS Revocaciones details
2012-08-13 Boletín Oficial del Registro Mercantil (Spain) Consejero: LANG LENTON ARTURO Ceses/Dimisiones details
2012-02-14 Boletín Oficial del Registro Mercantil (Spain) Importe reducción: 629,75 Euros. Resultante Suscrito: 382.500,00 Euros. Reducción de capital details
2011-08-30 Boletín Oficial del Registro Mercantil (Spain) Consejero: DECAUX JEAN SEBASTIAN Con.Delegado: DECAUX JEAN SEBASTIAN Presiden... Nombramientos details
2011-04-15 Boletín Oficial del Registro Mercantil (Spain) PROL DE LA CALLE SAN PAULO S/N - NAVE 5 POLIGONO I (PALMAS DE GRAN CANARIA (LAS. Cambio de domicilio social details
Hide historic records