Changes to our website — to find out why access to some data now requires a login, click here
The Open Database Of The Corporate World

LWI ELASTOMERS INTERNATIONAL SL

Company Number
82654765
Company Type
Sociedad Limitada
Jurisdiction
Spain
Controlling Company
WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIES CORPORATION
Registry Page
Please log in for link to primary source
Source Spanish Mercantile Registry, https://www.registradores.org/mercant..., 13 Jun 2011

Gazette notices

Date Publication Notice Classification
2018-06-06 Boletín Oficial del Registro Mercantil (Spain) Consejero: MASTALERZ JOHN ANTHONY Consejero: FETSKO III MICHAEL EDWARD Con.De... Nombramientos details
2018-06-06 Boletín Oficial del Registro Mercantil (Spain) Consejero: HILDUM KEITH PATRICK Consejero: MEYER DAVID JAMES Vicepresid.: HIL... Ceses/Dimisiones details
2012-07-26 Boletín Oficial del Registro Mercantil (Spain) Secretario: THOMPSON KIM ANNE Consejero: THOMPSON KIM ANNE Ceses/Dimisiones details
2014-03-11 Boletín Oficial del Registro Mercantil (Spain) PASEO RECOLETOS NUMERO 37-41, QUINTA PLANTA (MADRID). Cambio de domicilio social details
2014-10-09 Boletín Oficial del Registro Mercantil (Spain) Apoderado: VEGA PENICHET LOPEZ JUAN Revocaciones details
2014-11-19 Boletín Oficial del Registro Mercantil (Spain) Consejero: MEYER DAVID JAMES Con.Delegado: MEYER DAVID JAMES Presidente: MEYE... Ceses/Dimisiones details
2014-11-19 Boletín Oficial del Registro Mercantil (Spain) Consejero: WHITEFORD JOHN DOUGLAS Con.Delegado: WHITEFORD JOHN DOUGLAS Presid... Nombramientos details
2011-02-03 Boletín Oficial del Registro Mercantil (Spain) Consejero: LONGWOOD ELASTOMERS SA Consejero: THOMPSON KIM ANNE Consejero: WAT... Nombramientos details
2015-11-16 Boletín Oficial del Registro Mercantil (Spain) Consejero: MEYER DAVID JAMES Con.Delegado: MEYER DAVID JAMES Presidente: MEYE... Nombramientos details
2014-01-28 Boletín Oficial del Registro Mercantil (Spain) Consejero: LONGWOOD ELASTOMERS SA Consejero: SMITH GARY LYNN Consejero: WATER... Ceses/Dimisiones details
2014-01-28 Boletín Oficial del Registro Mercantil (Spain) Vicepresid.: SEITZ DAVID MICHAEL Vicepresid.: HILDUM KEITH PATRICK Consejero:... Nombramientos details
2015-11-16 Boletín Oficial del Registro Mercantil (Spain) Consejero: WHITEFORD JOHN DOUGLAS Con.Delegado: WHITEFORD JOHN DOUGLAS Presid... Ceses/Dimisiones details
2014-04-28 Boletín Oficial del Registro Mercantil (Spain) Apo.Sol.: SALAZAR FERNANDEZ JUAN CARLOS Apo.Sol.: BASCHWITZ RUBIO PABLO Nombramientos details
2013-05-30 Boletín Oficial del Registro Mercantil (Spain) C/ ALCALA 115 (MADRID). Cambio de domicilio social details
2011-02-03 Boletín Oficial del Registro Mercantil (Spain) Justificacion de no aprobacion de cuentas del ejercicio 2008 mediante certifi... Articulo 378.5 del Reglamento del Registro Mercantil details
2014-02-04 Boletín Oficial del Registro Mercantil (Spain) Consejero: SMITH GARY LYNN Consejero: WATERMAN DANA STEPHEN Consejero: LWI EL... Ceses/Dimisiones details
2014-01-28 Boletín Oficial del Registro Mercantil (Spain) Fecha de Cierre de Ejercicio: 31/12. 25. Cierre del Ejercicio.-. Modificaciones estatutarias details
2011-02-03 Boletín Oficial del Registro Mercantil (Spain) VsecrNoConsj: VEGA PENICHET LOPEZ GRACIELA Secretario: VEGA PENICHET LOPEZ JU... Ceses/Dimisiones details
2012-07-26 Boletín Oficial del Registro Mercantil (Spain) Consejero: SMITH GARY LYNN Nombramientos details
2011-02-07 Boletín Oficial del Registro Mercantil (Spain) Consejero: THOMPSON KIM ANNE Consejero: WATERMAN DANA STEPHEN Consejero: LWI ... Nombramientos details


* While we strive to keep this information correct and up-to-date, it is not the primary source, and the company registry (see source, above) should always be referred to for definitive information
Data on this page last changed February 29 2024

Problem/question about this data? Click here

API Open Data

For access please Log in / Sign up

OpenCorporates
A very different type of data company
Find out more